26
THE YUKON GAZETTE Printed by Authority of the Queen's Printer PARTS I AND II LA GAZETTE DU YUKON Imprimée sous l'autorité de l'Imprimeur de la Reine PARTIES I ET II Volume 36 Whitehorse, January 15, 2017 Number 1 Volume 36 Whitehorse, le 15 janvier 2017 Numéro 1

THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

  • Upload
    dinhnga

  • View
    244

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

THE YUKON GAZETTEPrinted by Authority of the Queen's Printer

PARTS I AND II

LA GAZETTE DU YUKONImprimée sous l'autorité de l'Imprimeur de la Reine

PARTIES I ET II

Volume 36 Whitehorse, January 15, 2017 Number 1

Volume 36 Whitehorse, le 15 janvier 2017 Numéro 1

Page 2: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

PART I PARTIE INOTICES / AVIS

DISSOLUTION BY THE REGISTRARPursuant to section 214 of the Business Corporations Act, a notice of intent to dissolve is hereby given to the following corporations.A Certificate of Dissolution will be issued should the corporation fail to submit all outstanding filings within 120 days of this notice.

535823 535823 Yukon Inc. 535822 Pure Nature Estates Inc.

535815 Glacier Gold Ltd. 535812 535812 Yukon Inc.

535627 535627 Yukon Inc. 535453 47151 Yukon Inc.

534883 45787 Yukon Inc. 534243 Druid Exploration Inc.

533590 43477 Yukon Inc. 533097 R. Smith Placer Mining Ltd.

532821 Claycliffs Investments Limited 532621 41431 Yukon Inc.

532025 40078 Yukon Inc. 531503 38989 Yukon Inc.

531502 Liard First Nation Development Corporation 527559 Corvus Corax Holdings Ltd.

523503 Solid Gold Communications Ltd. 523487 Unitech Sound & Lighting Inc.

522390 White Industries Ltd. 521087 J.A.E. Resources Incorporated

530428 37053 Yukon Inc. 535806 Northbound Expediting Ltd.

535804 Yukon Wilderness Mining & Exploration Inc. 535803 535803 Yukon Inc.

535617 Hunter Runter Investments Ltd. 535614 535614 Yukon Inc.

535436 Yukon Times Media Ltd. 534868 Red Tiger Mining Inc.

534852 Studio, Integrated Health and Fitness Inc., The 534168 Jarvis Street Saloon Ltd.

532564 41266 Yukon Inc. 532563 Leaping Feats Creative Danceworks Limited

532556 D. Sergeeva Professional Corporation 527486 Access Field Services Ltd.

526938 Vista Tek Ltd. 525474 Qiu's Restaurant Inc.

524675 Mopass Ventures Ltd. 520541 Delta International Corporation

535792 Northern Family Food Services Inc. 535791 Forrester Resources Corp.

535790 535790 Yukon Inc. 535789 535789 Yukon Inc.

535787 First Klas Resources Ltd. 535612 Next System International Holdings Limited

535376 47107 Yukon Inc. 534763 Solution Excavating Ltd.

534156 Rio Pino Minerals Inc. 534141 Silver Valley Mining Inc.

534133 Down To Earth Excavation Corp. 533403 Fred's Plumbing & Heating Inc.

531397 38780 Yukon Inc. 531390 Alcan Railink Inc.

530858 Divago Resources Corp. 527394 Modern Props Inc.

524047 N.C. Used Equipment Company Limited 535780 Sir Northernventures Ltd.

535778 535778 Yukon Inc. 535776 Brasenose Holdings Inc.

535585 535585 Yukon Inc. 535372 Leslie Leong Ent. Ltd.

533323 42861 Yukon Inc. 529220 Snowy Owl Energy Corp.

529007 33665 Yukon Inc. 528301 Triple S Services Ltd.

527563 Pro North Electric Ltd. 525286 13634 Yukon Inc.

523101 Thomas Electric Ltd. 521457 Mike Hogan Enterprises Ltd.

1 Partie I, 15 janvier 2017

Page 3: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

535769 535769 Yukon Inc. 535765 Hot Power Inc.

535764 Northern Legacy Energy Corp. 535758 535758 Yukon Inc.

535572 535572 Yukon Inc. 535331 Har-Dly Moving Inc.

535310 Maclean Integrated Services Incorporated 535306 46766 Yukon Inc.

534667 Sourdough Resources Inc. 534665 45369 Yukon Inc.

534046 Erik Group Retail Ltd. 532939 42344 Yukon Inc.

532935 42333 Yukon Inc. 532925 Northroc Drywall Ltd.

532390 Computer Nerds 4 Hire Ltd. 531868 39616 Yukon Inc.

531281 Cash Contracting Ltd. 531036 Finlayson Minerals Corporation

524526 Audio Specialties & Electronics Inc. 522468 Yukon Drilling & Blasting Ltd.

520328 Caron Diamond Drilling (1975) Limited 535751 535751 Yukon Inc.

535749 535749 Yukon Inc. 535746 MCK Professional Property Maintenance Ltd.

535745 Cartel Scientific International Inc. 535558 535558 Yukon Inc.

535263 46755 Yukon Inc. 533409 43224 Yukon Inc.

533374 43114 Yukon Inc. 532611 Sphere Resources Inc.

532363 40661 Yukon Inc. 531260 Filipina Cleaners Limited

530175 36470 Yukon Inc. 529553 Rabbit Creek Transport Inc.

526600 Gearjammer's Hotel Inc. 524123 Catalyst Communications Inc.

523984 11995 Yukon Inc. 521403 Mcfarlane Trading Co. Ltd.

535741 Faraway Yukon Corp. 535736 Motodrifters Rentals & Tours Ltd.

535731 Mack Built Contracting Inc. 535729 535729 Yukon Inc.

535244 46700 Yukon Inc. 533944 Earth Tek Drilling Ltd.

533213 Nokuyukon Holdings Ltd. 524417 Whispering Willows Records Inc.

523327 Icefield Instruments Inc. 522813 Community Motor Lodge Ltd.

535719 535719 Yukon Inc. 535714 Northern Power Projects Ltd.

535161 Castle Power Line Contractors Corp. 534530 Territorial Expediting Ltd.

534508 45116 Yukon Inc. 533296 Sunlit Yukon Intercultural Services Inc.

532229 40430 Yukon Inc. 531727 Cecil Lampi Industrial Teck Ltd.

526504 16901 Yukon Inc. 525791 Riel Rich Holdings Inc.

521223 Sally J. Co. Ltd. 521173 Ketza Enterprises Ltd.

535705 W Warmer Clothing Ltd. 535704 Robbyn's Street Grill Inc.

535701 Super Kid Learning Ltd. 535700 Super Car Protection Ltd.

535699 Super Heating System Ltd. 535696 W Winter Wear Ltd.

535694 Ready To Go Food Ltd. 535693 Z Snow Auto Ltd.

535692 HQ Organic Ltd. 535690 Leader Winter Wear Factory Ltd.

535680 Bikini Beverage Company Ltd. 535672 535672 Yukon Inc.

535671 Panda Panda Delivery Service Ltd. 534472 45050 Yukon Inc.

534461 Raymar Painting Corp. 533809 Timberline Resource Strategies Inc.

533806 Arthon Yukon Constructors Inc. 533266 Hyland Gold Corporation

532780 Protector Consulting (DBN) Inc. 531704 39341 Yukon Inc.

531694 Great Way Minerals Inc. 528691 Akita/Kaska Drilling Ltd.

528682 Legacy Mint Ltd. 527844 Blue Sky Wood Chipping Ltd.

522434 Wudtsi Lake Holdings Ltd. 522082 Studio North Ltd.

520438 Conde North Ventures Ltd. 535698 Northern Unlimited Travel Ltd.

Part I, January 15, 2017 2

Page 4: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

535666 D&A Development Ltd. 535661 Vertical Heli-Solutions Ltd.

535030 3-D Hardscapes Inc. 532163 Subvert Marketing Inc.

531610 39165 Yukon Inc. 531367 Atlantis Research and Development Inc.

529983 36129 Yukon Inc. 529982 Genietek Innovations Inc.

527219 Ivanhoe Energy Inc. 526377 16670 Yukon Inc.

523259 Top of The World Golf Course Ltd. 521975 Search North Ltd.

520808 French Hill Mining Corporation 535657 535657 Yukon Inc.

535653 Reid Mining Ltd. 535620 535620 Yukon Inc.

535472 Flightpass Travel Ltd. 534988 Yukon Solar Power Installation and Assembly Ltd.

534348 Yukon Jade and Gold Processing & Exporting Ltd 532690 41519 Yukon Inc.

529896 35887 Yukon Inc. 529276 34215 Yukon Inc.

529264 Maltby Systems Consulting Ltd. 525626 Wasgo Industries Limited

524881 Primrose Builders Ltd. 524863 12952 Yukon Inc.

523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd.

535633 Konde Cabs Limited 534941 46062 Yukon Inc.

534277 44335 Yukon Inc. 533124 Lambert Street Real Estate Holdings Inc.

526934 Ptarmigan Software Inc. 523816 Ketza River Holdings Ltd.

521372 Marten Creek Placers Ltd. 521224 Kluane R.V. Kampground Ltd.

519917 Acorn Auto Centre Ltd. 534891 45842 Yukon Inc.

530951 37988 Yukon Inc. 529129 33742 Yukon Inc.

527565 19783 Yukon Inc. 521768 Phillips N & D Enterprises Ltd.

531550 Upscale Downtown Living Incorporated 534940 46040 Yukon Inc.

526892 17990 Yukon Inc. 534842 45721 Yukon Inc.

534839 45677 Yukon Inc. 533568 43455 Yukon Inc.

533065 Big Day Video Productions Ltd. 527499 Pure Essence Books Ltd.

526145 Summex Mines Ltd. 525449 Hugh J. Monaghan and Associates, Incorporated

532591 41277 Yukon Inc. 535613 535613 Yukon Inc.

535608 Frow Holdings Ltd. 535606 535606 Yukon Inc.

535403 Rah Rah Gallery Ltd. 532534 41178 Yukon Inc.

531951 39935 Yukon Inc. 531929 39847 Yukon Inc.

527389 19222 Yukon Inc. 535593 535593 Yukon Inc.

535358 NND RTL Mining Services Corp. 531368 38736 Yukon Inc.

530254 36690 Yukon Inc. 525284 14118 Yukon Inc.

521925 Rose Perfect Inc. 534755 45556 Yukon Inc.

535300 46678 Yukon Ltd. 534771 Northern Hospital & Safety Supply Inc.

534037 Santana Construction & Consultant Ltd. 532386 40914 Yukon Inc.

530239 TND Motor Hotel Limited 530221 36569 Yukon Inc.

528259 Watson Lake Iron Works Ltd. 526676 Del Macmillan Holdings Ltd.

535545 535545 Yukon Inc. 529546 Kaldoni Northern Holdings Inc.

524484 Bostock Holdings Inc. 535541 Read Group Gold Corp.

535531 Dempster Korner Ltd. 535530 Jia Gold Inc.

535529 Aurum Geological Consultants Inc. 535189 Klondike Dredge Wood Inc.

534583 45215 Yukon Inc. 533899 44115 Yukon Inc.

533728 Van Every Logistics Ltd. 533351 Ampex Mining Ltd.

3 Partie I, 15 janvier 2017

Page 5: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

532307 Grosvenor Park Securities Inc. 530110 36382 Yukon Inc.

527148 527148 Yukon Inc. 520800 Frantic Follies Limited

535525 535525 Yukon Inc. 535520 535520 Yukon Inc.

535511 535511 Yukon Inc. 535508 535508 Yukon Inc.

535164 Emcorp Builders Ltd. 533316 43004 Yukon Inc.

528055 29870 Yukon Inc. 525815 15328 Yukon Inc.

524061 Yukon Instant Printing Ltd. 535502 535502 Yukon Inc.

533273 Kaska Horizon Land Team Development Ltd. 531693 39275 Yukon Inc.

531690 39242 Yukon Inc. 521304 Livingstone Placer Ltd.

520514 Davos Holdings Ltd. 535490 535490 Yukon Inc.

535038 Lone Moose Construction Consulting Ltd. 535034 Far Mountain Mining Ltd.

531637 Minto Creek Contracting Ltd. 529978 Yukon Mountain Woodworks Ltd.

527004 Puskas Consulting Services Inc. 523885 11621 Yukon Inc.

535474 Larj Holdings (Yukon) Inc. 535473 535473 Yukon Inc.

533702 43620 Yukon Inc. 526964 Stephen J. Mills Consultants Inc.

525360 Liard Plywood and Lumber Manufacturing Inc. 522545 4141 Yukon Limited

520978 Triple 'H' Holdings Inc. 535468 Trinity NND Helicopters Corp.

533127 42586 Yukon Inc. 532641 Riverjet Safaris Yukon Limited

532076 40188 Yukon Inc. 529856 35920 Yukon Inc.

529207 Portland Canal Aggregates Corporation 500056 4625 Yukon Limited

535451 47250 Yukon Inc. 534892 45919 Yukon Inc.

533621 43499 Yukon Inc. 529778 Ansen Manufacturing Corporation

527537 19728 Yukon Inc. 526447 Mandalay Ventures Inc.

522583 6077 Yukon Ltd. 522368 Whitehorse Coal Corporation

521819 Ptarmigan Tarmac Ltd. 535425 High Country Rentals Ltd.

535417 Little Berry Productions Incorporated 534836 45710 Yukon Inc.

534163 44555 Yukon Inc. 530869 37768 Yukon Inc.

530320 No Name Resources Inc. 521021 H.R. Vance Construction Ltd.

535400 Tru North Outdoor Adventures Inc. 534137 44544 Yukon Inc.

534132 Curious Buddies Daycare & Nightcare Inc. 532497 41046 Yukon Inc.

531948 Airport Gifts and Bookings Ltd. 534719 45512 Yukon Inc.

534709 45479 Yukon Inc. 534696 Nutech Exploration Services Ltd.

532970 42421 Yukon Inc. 531928 39836 Yukon Inc.

531369 Northern Garments Inc. 530837 Monarch Mining Services Limited

527342 19057 Yukon Inc. 526731 Bruce Community Development Consultants Ltd.

535337 46975 Yukon Inc. 534049 Sourdough Cafe Ltd.

531891 39737 Yukon Inc. 530771 Robert and Laurie Freight Services Inc.

526105 Liard Fire Suppression Inc. 522566 5450 Yukon Ltd.

519988 Alternative Industries & Development Limited 535289 46843 Yukon Inc.

535266 46744 Yukon Inc. 535262 Angela Neufeld, Registered Psychologist, Inc.

535250 Teresita De Hacienda Properties Inc. 534611 Fulton Management Consulting Ltd.

533983 Gold Rain Resources Inc. 531846 Nansen Gold Resources Inc.

529530 Glacier Gems Inc. 526572 Wintech Ski & Snowboard Academy Ltd.

522065 St. Cyr Range Mineral Explorations Ltd. 520240 Bushland Equipment Inc.

Part I, January 15, 2017 4

Page 6: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

535239 Avalanche Fitness Inc. 535234 46689 Yukon Inc.

535222 First Nations Alliance Construction Group Inc. 535212 Sean & Jim's Water Services Ltd.

535209 Dun Plumbing & Heating Ltd. 534588 Mckinney Placers Ltd.

533943 Soda Creek Resources Corp. 532860 42146 Yukon Inc.

531767 Flying Pisces Mobile Bistro Inc 531181 Lardon Boutique Ltd.

530104 Summit Hockey Schools Inc. 529480 34721 Yukon Inc.

529476 Kearah Environmental Contracting Inc. 527116 18254 Yukon Inc.

525135 Triplets To Support Mining Ltd. 524455 Lomak North Corp.

523351 Trimate Construction Limited 520218 Brewster Enterprises Limited

535157 Bros Exploration Ltd. 535146 Revolution Mechanical Services Inc.

535129 Rafex Exploration Incorporated 534513 Fluid Management Technologies Inc.

533844 Loekslog Homes Ltd. 533331 P. Laureijs MD Professional Corp.

532827 41783 Yukon Inc. 532306 Bruce Habberfield (07) Inc.

532239 Black Horse Racing Ltd. 531815 39517 Yukon Inc.

531721 Golden Hill Ventures Ltd. 530037 36019 Yukon Inc.

528725 33126 Yukon Inc. 528710 33115 Yukon Inc.

525802 14954 Yukon Inc. 519911 Access Network Corporation

535121 Bonanza Mining Services Ltd. 535119 Purcell Industries (Yukon) Limited

535105 46370 Yukon Inc. 535103 46414 Yukon Inc.

535102 46403 Yukon Inc. 535078 46128 Yukon Inc.

535077 46304 Yukon Inc. 530959 Tanana Exploration Inc.

529379 Five Stones Holdings Ltd. 527054 18320 Yukon Inc.

525734 15031 Yukon Inc. 523927 RBG Plumbing & Heating, Ltd.

521668 O.E.L. Electric Limited 535066 Lihao Mining Equipment Import Inc.

535047 Toughstone Diamond Drilling Inc. 535045 46051 Yukon Inc.

535044 46150 Yukon Inc. 535027 Go4Gold Mining Corp.

533742 Apologies Productions (YT) Inc. 532754 White Digital Media (Canada) Inc.

527002 Pro Minerals Ltd. 523578 Alwarid and Associates Consulting Limited

521608 Northern Cadworks Ltd. 520241 Bushland Exploration Inc.

534957 46095 Yukon Inc. 534359 Anonna Consultants Ltd.

533218 Keno Hill Exploration Corp. 532101 40221 Yukon Inc.

530466 37174 Yukon Inc. 529918 Wet Coast Capital Corp.

529913 Wet Coast Management Corp. 529277 34171 Yukon Inc.

526331 16593 Yukon Inc. 522426 Woodbine Marketing Corporation

534945 46073 Yukon Inc. 534926 Fireweed Painting Limited

534925 45996 Yukon Inc. 533666 Montana Highway Services Inc.

533656 Bird House Eatery & Gifts Inc.,The 533642 Tundra Trax Auto Installations Limited

531514 39000 Yukon Inc. 529217 Hadley Transportation Ltd.

534906 45897 Yukon Inc. 534882 45853 Yukon Inc.

534869 Kaos Construction Contracting Ltd. 534866 Ruby Range Mining Ltd.

533759 43653 Yukon Inc. 533616 Wyatt Star Holdings Inc.

530947 39700 Yukon Inc. 528100 Vancadia Capital Corporation

526216 Bickers Homes Ltd. 526187 South Yukon Forest Corp.

524207 Hougen's Watson Lake Ltd. 523497 Sanbear Enterprises Ltd.

5 Partie I, 15 janvier 2017

Page 7: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

535159 46524 Yukon Inc. 534846 45732 Yukon Inc.

531990 Honey Do Residential Maintenance & Cleaning Inc. 521033 Hydra Ventures Limited

534798 Hamilton Boucher Media Inc. 532491 41079 Yukon Inc.

530850 Cornerstone Gas Corporation 530280 36811 Yukon Inc.

527407 19343 Yukon Inc. 525382 Doug Hogan Enterprises Limited

534739 45314 Yukon Inc. 534722 Black Raven Delivery Ltd.

534721 Eyla's Distribution Canada Ltd. 534705 Borderline Environmental Services Ltd.

534697 Ross A. Mcleod Investment Corp. 534084 44456 Yukon Inc.

532445 Cassiar Creek Holdings Ltd. 531917 Tescon Development Corporation

531915 Chiczenfun Life Design Inc. 531375 Indivisual Films Inc.

530250 36646 Yukon Inc. 526720 Golden Gate Resources Ltd.

525761 Creative Hair Design Inc. 533457 Grunt Action Inc.

531875 39649 Yukon Inc. 528933 Dawson Peaks Adventure Company Ltd.

522464 Yukon Business Services Limited 534643 Nordem Disaster & Emergency Management Inc.

534600 Norseman Exploration Services Inc. 534596 45193 Yukon Inc.

532375 Goat Hill Property Management Inc. 531823 50 Mile Placer Inc.

529724 Bonanza Inn 2002 Corp. 534553 Sidehill Exploration Ltd.

534539 22249 Yukon Inc. 533341 43044 Yukon Inc.

532855 42124 Yukon Inc. 524420 12380 Yukon Inc.

521604 Northern Analytical Laboratories Ltd. 521222 Kluane Mechanical Contractors Ltd.

520613 Dredge Master Gold Ltd. 534511 E-Biz Placer & Explorations Limited

534507 Big Picture Investments Corp. 534500 45039 Yukon Inc.

534488 Dragonfly Properties Inc. 533849 Canadian Alternative Resources Inc.

532841 41794 Yukon Inc. 531759 Maketraxx Industries Ltd.

527898 28143 Yukon Inc. 534450 Zamarat Yukon Inc.

533815 Johnson's Crossing Therapeutic Living Centre Inc. 532793 Yukon-Shaanxi Mining Company Inc.

532782 41684 Yukon Inc. 532198 40353 Yukon Inc.

531162 Whitehorse Travel Ltd. 530580 Sinclair and Associates Ltd.

530020 Mountain Avens Montessori School Limited 528668 Svb Nickel Company Ltd.

525739 Digital Stream Inc. 520668 Empire Creek Mining Ltd.

534392 Powder Lords Inc. 534388 44918 Yukon Inc.

534382 44929 Yukon Inc. 532711 New Brikon Metals Corp.

521931 Ross River Service Centre Ltd. 520570 Eldorado Placers Ltd.

519971 Alkan Electric Ltd. 534375 44896 Yukon Inc.

534337 Moe's Yukon Ranch Adventures Ltd 534336 Dezadeash Lake Hay Ranch Ltd.

531020 Zola's Cafe Dore Inc. 529267 34127 Yukon Inc.

522013 Sinolter Inc. 521655 Nugget Charlie Company Ltd.

520195 Border Gold Mines Ltd. 534289 Concorde Bed & Bath Inc.

533963 44258 Yukon Inc. 533640 DSG Building Construction Group Incorporated

532059 40144 Yukon Inc. 532058 Blaine D. Anderson C.A. Ltd.

524818 Walter Wilhelm Ltd. 524804 Mira Lobster Co. Ltd.

534267 44698 Yukon Inc. 534251 Andre's Welding Services Inc.

532614 41409 Yukon Inc. 532602 O & G Global Petroleum Services Inc.

532592 41321 Yukon Inc. 532046 Northern Documentary Inc.

Part I, January 15, 2017 6

Page 8: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

532034 40056 Yukon Inc. 532015 Flat Creek Ranch Ltd.

521810 Primrose Wilderness Encounters Ltd. 521095 Jayram Holdings Ltd.

534206 Harmony Mobility Network Corp. 534201 Run Construction Ltd.

534197 Hunter Mine Services Inc. 534165 Yukon Sunny Food Incorporation

533089 Celtic Harp Counselling Agency Limited 530311 Forgent Networks Canada, Inc.

523157 Yukon Taxi Service Ltd. 522845 Skylight Painting Ltd.

534146 Alpha Dog Security Corporation 534119 RPM Construction Management Ltd.

533462 Bluepoint Data, Inc. 531936 39869 Yukon Inc.

530860 Southern Lake Developing Inc. 529688 35315 Yukon Inc.

528721 Mid Arctic Enterprises Inc. 533826 MGB Network Investments Inc.

527807 Madley's Bigway Ltd. 529538 34941 Yukon Inc.

532846 41816 Yukon Inc 530733 Versatile Rentals Plus Ltd.

523589 Tripp Travel Ltd. 535488 I-HRDC International Human Resources Development ofCanada Ltd.

Fred Pretorious, Registrar of Corporations

Yukon GazettePublished by the Authority of the Queen's Printer, Yukon

Notice is given that a survey has been made of placer claims P 06280 and P 06281 (Claim 7 and Claim 8) on the Right Fork ofEureka Creek, Quad 115 O/10, Latitude 63° 35', Longitude 138° 52' (approximately) under instructions issued by direction of theMinister. Such survey will be accepted as defining absolutely the boundaries of the claims surveyed unless it is protested asprovided in Section 39 of the Placer Mining Act.

The plan of survey can be viewed at the Dawson Mining Recorder's Office, 1242 Front Street, Dawson City, Yukon Territory.

Any protest to the plan of survey above noted will be via the Dawson Mining Recorder's Office, 1242 Front Street, Dawson City,Yukon Territory.

Date: August 1, 2016

7 Partie I, 15 janvier 2017

Page 9: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

APPOINTMENTS NOMINATIONS

FILEDO.I.C. 2016/177 13 December, 2016

ARCHIVES ACT

Pursuant to section 2 of the Archives Act, the Commissionerin Executive Council orders

1.

Ian Burnett is appointed as the archivist.

2.

This Order comes into force on January 1, 2017.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/177 13 décembre 2016

LOI SUR LES ARCHIVES

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article2 de la Loi sur les archives, décrète :

1.

Ian Burnett est nommé à titre d'archiviste.

2.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier2017.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

Part I, January 15, 2017 8

Page 10: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDO.I.C. 2016/178 13 December, 2016

ASSESSMENT AND TAXATION ACT

Pursuant to section 19 and subsection 23(1) of theAssessment and Taxation Act, the Commissioner inExecutive Council orders

1.

An Assessment Review Board, to be known as theCentral Yukon Assessment Review Board, isestablished for all that part of Yukon(a) lying to the south of 61 degrees 45 minutes

north latitude, west of 131 degrees westlongitude and east of 137 degrees westlongitude;

(b) lying to the south of 63 degrees north latitude,west of 136 degrees west longitude, north of62 degrees north latitude, and east of 138degrees west longitude;

(c) lying to the south of 62 degrees north latitude,west of 136 degrees west longitude, north of61 degrees 45 minutes north latitude and eastof 137 degrees west longitude.

2.

The following persons are appointed as membersof the Central Yukon Assessment Review Board

Tamara Goeppel - chair

Rick Reaume - vice-chair

Don Inverarity - member.

3.

The Central Yukon Assessment Review Boardshall commence sitting to hear complaintsagainst the assessment roll prior to February 15,2017.

4.

This order(a) comes into force on the later of

(i) the day it is filed with the registrar ofregulations under the Regulations Act,and

(ii) January 1, 2017; and

(b) expires on December 31, 2017.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/178 13 décembre 2016

LOI SUR L'ÉVALUATION ET LA TAXATION

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article19 et au paragraphe 23(1) de la Loi sur l'évaluation et lataxation, décrète :

1.

Est constitué un conseil de révision desévaluations appelé le Conseil de révision desévaluations foncières du centre du Yukon, pour lapartie du Yukon située :(a) au sud de la latitude 61o 45' Nord, à l'ouest de

la longitude 131o Ouest et à l'est de lalongitude 137o Ouest;

(b) au sud de la latitude 63o Nord, à l'ouest de lalongitude 136o Ouest, au nord de la latitude62o Nord et à l'est de la longitude 138o Ouest;

(c) au sud de la latitude 62o Nord, à l'ouest de lalongitude 136o Ouest, au nord de la latitude61o 45' Nord et à l'est de la longitude 137oOuest.

2.

Les membres du Conseil de révision desévaluations foncières du centre du Yukon sont :

Tamara Goeppel - présidente

Rick Reaume - vice-président

Don Inverarity - membre.

3.

Le Conseil de révision des évaluations foncièresdu centre du Yukon doit débuter les séancesd'audition des plaintes relatives au rôled'évaluation foncière avant le 15 février 2017.

4.

Le présent décret :(a) entre en vigueur :

(i) soit à la date de son dépôt auprès duregistraire des règlements en vertu de laLoi sur les règlements,

(ii) soit le 1er janvier 2017, si cette date estpostérieure;

(b) expire le 31 décembre 2017.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

9 Partie I, 15 janvier 2017

Page 11: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDO.I.C. 2016/179 13 December, 2016

ASSESSMENT AND TAXATION ACT

Pursuant to section 19 and subsection 23(1) of theAssessment and Taxation Act, the Commissioner inExecutive Council orders

1.

An Assessment Review Board, to be known as theCentral East Yukon Assessment Review Board, isestablished for all that part of Yukon lying to theeast of 136 degrees west longitude, south of 63degrees north latitude, west of 131 degrees westlongitude and north of 61 degrees 45 minutesnorth latitude.

2.

The following persons are appointed as membersof the Central East Yukon Assessment ReviewBoard

Julia Salo - chair

Lester Boyle - vice-chair

Debbie Carreau - member

Gary Jones - alternate member.

3.

The Central East Yukon Assessment Review Boardshall commence sitting to hear complaintsagainst the assessment roll prior to February 15,2017.

4.

This order(a) comes into force on the later of

(i) the day it is filed with the registrar ofregulations under the Regulations Act,and

(ii) January 1, 2017; and

(b) expires on December 31, 2017.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/179 13 décembre 2016

LOI SUR L'ÉVALUATION ET LA TAXATION

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article19 et au paragraphe 23(1) de la Loi sur l'évaluation et lataxation, décrète :

1.

Est constitué un conseil de révision desévaluations appelé le Conseil de révision desévaluations foncières du centre-est du Yukon,pour la partie du Yukon située à l'est de lalongitude 136o Ouest et au sud de la latitude 63oNord, ainsi que pour la partie du Yukon située àl'ouest de la longitude 131o Ouest et au nord dela latitude 61o 45' Nord.

2.

Les membres du Conseil de révision desévaluations foncières du centre-est du Yukonsont :

Julia Salo - présidente

Lester Boyle - vice-président

Debbie Carreau - membre

Gary Jones - membre suppléant.

3.

Le Conseil de révision des évaluations foncièresdu centre-est du Yukon doit débuter les séancesd'audition des plaintes relatives au rôled'évaluation foncière avant le 15 février 2017.

4.

Le présent décret :(a) entre en vigueur :

(i) soit à la date de son dépôt auprès duregistraire des règlements en vertu de laLoi sur les règlements,

(ii) soit le 1er janvier 2017, si cette date estpostérieure;

(b) expire le 31 décembre 2017.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

Part I, January 15, 2017 10

Page 12: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDO.I.C. 2016/180 13 December, 2016

ASSESSMENT AND TAXATION ACT

Pursuant to section 19 and subsection 23(1) of theAssessment and Taxation Act, the Commissioner inExecutive Council orders

1.

An Assessment Review Board, to be known as theNorth Yukon Assessment Review Board, isestablished for all that part of Yukon lying to thenorth of 63 degrees north latitude.

2.

The following persons are appointed as membersof the North Yukon Assessment Review Board

Bob Laking - chair

Margaret Kormendy - vice-chair

Lambert Curzon - member.

3.

The North Yukon Assessment Review board shallcommence sitting to hear complaints against theassessment roll prior to February 15, 2017.

4.

This order(a) comes into force on the later of

(i) the day it is filed with the registrar ofregulations under the Regulations Act,and

(ii) January 1, 2017; and

(b) expires on December 31, 2017.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/180 13 décembre 2016

LOI SUR L'ÉVALUATION ET LA TAXATION

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article19 et au paragraphe 23(1) de la Loi sur l'évaluation et lataxation, décrète :

1.

Est constitué un conseil de révision desévaluations appelé le Conseil de révision desévaluations foncières du nord du Yukon, pour lapartie du Yukon située au nord de la latitude 63oNord.

2.

Les membres du Conseil de révision desévaluations foncières du nord du Yukon sont :

Bob Laking - président

Margaret Kormendy - vice-présidente

Lambert Curzon - membre.

3.

Le Conseil de révision des évaluations foncièresdu nord du Yukon doit débuter les séancesd'audition des plaintes relatives au rôled'évaluation foncière avant le 15 février 2017.

4.

Le présent décret :(a) entre en vigueur :

(i) soit à la date de son dépôt auprès duregistraire des règlements en vertu de laLoi sur les règlements,

(ii) soit le 1er janvier 2017, si cette date estpostérieure;

(b) expire le 31 décembre 2017.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

11 Partie I, 15 janvier 2017

Page 13: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDO.I.C. 2016/181 13 December, 2016

ASSESSMENT AND TAXATION ACT

Pursuant to section 19 and subsection 23(1) of theAssessment and Taxation Act, the Commissioner inExecutive Council orders

1.

An Assessment Review Board, to be known as theSoutheast Yukon Assessment Review Board, isestablished for all that part of Yukon lying to theeast of 131 degrees west longitude and south of 63degrees north latitude.

2.

The following persons are appointed as membersof the Southeast Yukon Assessment Review Board

Jim Holt - chair

Gord Sundby - vice-chair

Kathy Dyke - member

John Devries - alternate member.

3.

The Southeast Yukon Assessment Review Boardshall commence sitting to hear complaintsagainst the assessment roll prior to February 15,2017.

4.

This order(a) comes into force on the later of

(i) the day it is filed with the registrar ofregulations under the Regulations Act,and

(ii) January 1, 2017; and

(b) expires on December 31, 2017.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/181 13 décembre 2016

LOI SUR L'ÉVALUATION ET LA TAXATION

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article19 et au paragraphe 23(1) de la Loi sur l'évaluation et lataxation, décrète :

1.

Est constitué un conseil de révision desévaluations appelé le Conseil de révision desévaluations foncières du sud-est du Yukon, pourla partie du Yukon située à l'est de la longitude131o Ouest et au sud de la latitude 63o Nord.

2.

Les membres du Conseil de révision desévaluations foncières du sud-est du Yukon sont :

Jim Holt - président

Gord Sundby - vice-président

Kathy Dyke - membre

John Devries - membre suppléant.

3.

Le Conseil de révision des évaluations foncièresdu sud-est du Yukon doit débuter les séancesd'audition des plaintes relatives au rôled'évaluation foncière avant le 15 février 2017.

4.

Le présent décret :(a) entre en vigueur :

(i) soit à la date de son dépôt auprès duregistraire des règlements en vertu de laLoi sur les règlements,

(ii) soit le 1er janvier 2017, si cette date estpostérieure;

(b) expire le 31 décembre 2017.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

Part I, January 15, 2017 12

Page 14: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDO.I.C. 2016/182 13 December, 2016

ASSESSMENT AND TAXATION ACT

Pursuant to section 19 and subsection 23(1) of theAssessment and Taxation Act, the Commissioner inExecutive Council orders

1.

An Assessment Review Board, to be known as theSouthwest Yukon Assessment Review Board, isestablished for all that part of Yukon lying to thesouth of 63 degrees north latitude and west of 138degrees west longitude together with that partlying to the south of 62 degrees north latitude,west of 137 degrees west longitude and east of 138degrees west longitude.

2.

The following persons are appointed as membersof the Southwest Yukon Assessment ReviewBoard

Debbie Hotte - chair

TJ Grantham - vice-chair

Danielle Drummond - member

Martin Eckervogt - alternate member.

3.

The Southwest Yukon Assessment Review Boardshall commence sitting to hear complaintsagainst the assessment roll prior to February 15,2017.

4.

This order(a) comes into force on the later of

(i) the day it is filed with the registrar ofregulations under the Regulations Act,and

(ii) January 1, 2017; and

(b) expires on December 31, 2017.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/182 13 décembre 2016

LOI SUR L'ÉVALUATION ET LA TAXATION

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article19 et au paragraphe 23(1) de la Loi sur l'évaluation et lataxation, décrète :

1.

Est constitué un conseil de révision desévaluations appelé le Conseil de révision desévaluations foncières du sud-ouest du Yukon,pour la partie du Yukon située au sud de la latitude63o Nord et à l'ouest de la longitude 138o Ouest,ainsi que pour la partie située au sud de la latitude62o Nord, à l'ouest de la longitude 137o Ouest età l'est de la longitude 138o Ouest.

2.

Les membres du Conseil de révision desévaluations foncières du sud-ouest du Yukonsont :

Debbie Hotte - présidente

TJ Grantham - vice-président

Danielle Drummond - membre

Martin Eckervogt - membre suppléant.

3.

Le Conseil de révision des évaluations foncièresdu sud-ouest du Yukon doit débuter les séancesd'audition des plaintes relatives au rôled'évaluation foncière avant le 15 février 2017.

4.

Le présent décret :(a) entre en vigueur :

(i) soit à la date de son dépôt auprès duregistraire des règlements en vertu de laLoi sur les règlements,

(ii) soit le 1er janvier 2017, si cette date estpostérieure;

(b) expire le 31 décembre 2017.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

13 Partie I, 15 janvier 2017

Page 15: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDO.I.C. 2016/183 13 December, 2016

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

Whereas, under section 3 of the Financial AdministrationAct, there is a committee of the Executive Council called themanagement board which consists of the Minister of Financeas chair and other Ministers appointed by the Commissionerin Executive Council, therefore; Pursuant to subsections 3(1)and (2) of the Financial Administration Act, theCommissioner in Executive Council orders

1.

Ranj Pillai is appointed as alternate chair of theManagement Board.

2.

Ranj Pillai is appointed as a member of theManagement Board.

3.

John Streicker is appointed as an alternatemember of the Management Board for Ranj Pillai.

4.

Tracy-Anne McPhee is appointed as a member ofthe Management Board.

5.

Pauline Frost is appointed as an alternate memberof the Management Board for Tracy-AnneMcPhee.

6.

Order-in-Council 2011/137 is repealed.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/183 13 décembre 2016

LOI SUR LA GESTION DES FINANCESPUBLIQUES

Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la gestion desfinances publiques, il existe un comité du Conseil exécutifappelé le Conseil de gestion qui est composé du ministre desFinances à titre de président et d'autres ministres nomméspar le commissaire en conseil exécutif, à ces causes :Conformément aux paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur lagestion des finances publiques, le commissaire en conseilexécutif décrète :

1.

Ranj Pillai est nommé président suppléant duConseil de gestion.

2.

Ranj Pillai est nommé membre du Conseil degestion.

3.

John Streicker est nommé membre suppléant duConseil de gestion pour Ranj Pillai.

4.

Tracy-Anne McPhee est nommée membre duConseil de gestion.

5.

Pauline Frost est nommée membre suppléant duConseil de gestion pour Tracy-Anne McPhee.

6.

Pauline Frost est nommée membre suppléant duConseil de gestion pour Tracy-Anne McPhee.

7.

Le Décret 2011/137 est abrogé.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

Part I, January 15, 2017 14

Page 16: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDO.I.C. 2016/184 13 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACT

Pursuant to section 3 of the Government Organisation Act,the Commissioner in Executive Council orders

1.

Ministers are appointed as acting Ministers inaccordance with the table in the attachedSchedule, such that during the absence orincapacity of a Minister identified in column A ofthe table, each of the Minister's responsibilitiesidentified in column B of the table is assumed

(a) by the Minister (referred to in this Order as the "first acting Minister" for the responsibility) identified for the responsibility in column C of the table; or

(b) during the absence or incapacity of the first acting Minister, by the Minister identified for the responsibility in column D of the table.

2.

Order-in-Council 2015/18 is repealed.

Dated at Whitehorse, Yukon this 13 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET 2016/184 13 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article3 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, décrète :

1.

Les ministres sont nommés à titre de ministressuppléants en conformité avec le tableauparaissant en annexe pour faire en sorte qu'en casd'absence ou d'empêchement du ministreidentifié dans la colonne A du tableau, lesresponsabilités du ministre identifiées dans lacolonne B du tableau soient assumées :

a) par le ministre (le « ministre suppléant principal » pour l'application du présent décret) désigné pour cette responsabilité dans la colonne C du tableau;

b) en cas d'absence ou d'empêchement du ministre suppléant principal, par le ministre désigné pour cette responsabilité dans la colonne D du tableau.

2.

Le Décret 2015/18 est abrogé.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 13 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

15 Partie I, 15 janvier 2017

Page 17: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

COMMISSIONER'S ORDERDÉCRETS DU COMMISSAIRE

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/03 3 December, 2016

YUKON ACT (CANADA)

Pursuant to section 8 of the Yukon Act (Canada), andparagraph 2(1)(a) of the Government Organisation Act, theCommissioner orders

1.

The appointment of Darrell Thomas Pasloski as amember and President of the Executive Councilof Yukon made by Commissioner's Order2011/13 is revoked.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/03 3 décembre 2016

LOI SUR LE YUKON (CANADA)

Conformément à l'article 8 de la Loi sur le Yukon (Canada),et a l'alinéa 2(1)a) de la Loi sur l'organisation dugouvernement, le commissaire ordonne :

1.

La nomination de Darrell Thomas Pasloski, à titrede membre et président du Conseil exécutif duYukon, effectuée par le Décret du commissaire2011/13, est révoquée.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/04 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

1.

The appointment of Darrell Thomas Pasloski as amember of the Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of the ExecutiveCouncil Office and Minister of Finance made byCommissioner's Order 2011/14 is revoked.

2.

The appointment of Brad Cathers as a member ofthe Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of Justice and Ministerresponsible for the Yukon DevelopmentCorporation and the Yukon Energy Corporationmade by Commissioner's Order 2015/02 isrevoked.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/04 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), à l'alinéa 2(1)b) et à l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

1.

La nomination de Darrell Thomas Pasloski à titrede membre du Conseil exécutif du Yukon, deministre responsable du Conseil exécutif et deministre responsable du ministère des Finances,effectuée par le Décret du commissaire 2011/14,est révoquée.

2.

La nomination de Brad Cathers à titre de membredu Conseil exécutif du Yukon, de ministre de laJustice et de ministre responsable de la Société dedéveloppement du Yukon et de la Sociétéd'énergie du Yukon, effectuée par le Décret ducommissaire 2015/02, est révoquée.

Part I, January 15, 2017 16

Page 18: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

3.

The appointment of Currie Dixon as a member ofthe Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of Community Servicesand Minister of the Public Service Commissionmade by Commissioner's Order 2015/03 isrevoked.

4.

The appointment of Doug Graham as a memberof the Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of Education made byCommissioner's Order 2015/04 is revoked.

5.

The appointment of Stacey Hassard as a memberof the Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of EconomicDevelopment, Minister responsible for the YukonHousing Corporation and Minister responsiblefor the Yukon Liquor Corporation made byCommissioner's Order 2015/05 is revoked.

6.

The appointment of Wade Istchenko as a memberof the Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of Environment madeby Commissioner's Order 2015/06 is revoked.

7.

The appointment of Scott Kent as a member of theExecutive Council of Yukon with responsibility asMinister of Energy, Mines and Resources andMinister of Highways and Public Works made byCommissioner's Order 2015/07 is revoked.

8.

The appointment of Mike Nixon as a member ofthe Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of Health and SocialServices and Minister responsible for the Workers'Compensation Health and Safety Board, made byCommissioner's Order 2015/08 is revoked.

9.

The appointment of Elaine Elizabeth Taylor as amember of the Executive Council of Yukon withresponsibility as Minister of Tourism and Culture,Minister responsible for the Women'sDirectorate, and Minister responsible for theFrench Language Services Directorate made byCommissioner's Order 2015/09 is revoked.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

3.

La nomination de Currie Dixon à titre de membredu Conseil exécutif du Yukon, de ministre desServices aux collectivités et de ministreresponsable de la Commission de la fonctionpublique, effectuée par le Décret du commissaire2015/03, est révoquée.

4.

La nomination de Doug Graham à titre demembre du Conseil exécutif du Yukon et deministre de l'Éducation, effectuée par le Décret ducommissaire 2015/04, est révoquée.

5.

La nomination de Stacey Hassard à titre demembre du Conseil exécutif du Yukon, deministre du Développement économique, deministre responsable de la Société d'habitation duYukon et de ministre responsable de la Société desalcools du Yukon, effectuée par le Décret ducommissaire 2015/05, est révoquée.

6.

La nomination de Wade Istchenko à titre demembre du Conseil exécutif du Yukon et deministre de l'Environnement, effectuée par leDécret du commissaire 2015/06, est révoquée.

7.

La nomination de Scott Kent à titre de membre duConseil exécutif du Yukon, de ministre del'Énergie, des Mines et des Ressources et deministre de la Voirie et des Travaux publics,effectuée par le Décret du commissaire 2015/07,est révoquée.

8.

La nomination de Mike Nixon à titre de membredu Conseil exécutif du Yukon, de ministre de laSanté et des Affaires sociales et de ministreresponsable de la Commission de la santé et de lasécurité au travail, effectuée par le Décret ducommissaire 2015/08, est révoquée.

9.

La nomination d'Elaine Elizabeth Taylor à titre demembre du Conseil exécutif du Yukon, deministre du Tourisme et de la Culture, de ministreresponsable du Bureau de promotion des intérêtsde la femme et de ministre responsable de laDirection des services en français, effectuée par leDécret du commissaire 2015/09, est révoquée.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

17 Partie I, 15 janvier 2017

Page 19: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/05 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

Pursuant to section 8 of the Yukon Act (Canada), andparagraph 2(1)(a) of the Government Organisation Act, theCommissioner orders

SANDY SILVER

is appointed as a member and President of the ExecutiveCouncil of Yukon.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/05 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Conformément à l'article 8 de la Loi sur le Yukon (Canada),et à l'alinéa 2(1)a) de la Loi sur l'organisation dugouvernement, le commissaire ordonne le commissaireordonne :

SANDY SILVER

est nommé membre et président du Conseil exécutif duYukon.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/06 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

SANDY SILVER

is the member of the Executive Council withresponsibility as Minister of the Executive Council Office,and; Minister of Finance.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/06 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), et à l'alinéa 2(1)b) et l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

SANDY SILVER

est membre du Conseil exécutif et assume lesresponsabilités suivantes : Ministre responsable duConseil exécutif; Ministre responsable du ministère desFinances.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

Part I, January 15, 2017 18

Page 20: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/07 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

RANJ PILLAI

is appointed as a member of the Executive Council withresponsibility as Minister of Energy, Mines andResources; Minister of Economic Development; andMinister responsible for the Yukon DevelopmentCorporation and the Yukon Energy Corporation.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/07 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), et à l'alinéa 2(1)b) et l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

RANJ PILLAI

est nommé membre du Conseil exécutif et assume lesresponsabilités suivantes : ministre de l'Énergie, desMines et des Ressources; ministre du Développementéconomique; ministre responsable de la Société dedéveloppement du Yukon et de la Société d'énergie duYukon.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/08 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

TRACY-ANNE MCPHEE

is appointed as a member of the Executive Council withresponsibility as Minister of Education; and Minister ofJustice.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/08 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), et à l'alinéa 2(1)b) et l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

TRACY-ANNE MCPHEE

est nommée membre du Conseil exécutif et assume lesresponsabilités suivantes : ministre de l'Éducation;ministre de la Justice.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

19 Partie I, 15 janvier 2017

Page 21: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/09 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

JOHN STREICKER

is appointed as a member of the Executive Council withresponsibility as Minister of Community Services;Minister responsible for the French Language ServicesDirectorate; and Minister responsible for the YukonLiquor Corporation and the Yukon Lottery Commission.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/09 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), et à l'alinéa 2(1)b) et l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

JOHN STREICKER

est nommé membre du Conseil exécutif et assume lesresponsabilités suivantes : ministre des Services auxcollectivités; ministre responsable de la Direction desservices en français; ministre responsable de la Société desalcools du Yukon et de la Commission des loteries duYukon.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/10 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

PAULINE FROST

is appointed as a member of the Executive Council withresponsibility as Minister of Health and Social Services;Minister of Environment; and Minister responsible forthe Yukon Housing Corporation.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/10 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), et à l'alinéa 2(1)b) et l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

PAULINE FROST

est nommée membre du Conseil exécutif et assume lesresponsabilités suivantes : ministre de la Santé et desAffaires sociales; ministre de l'Environnement; ministreresponsable de la Société d'habitation du Yukon.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

Part I, January 15, 2017 20

Page 22: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/11 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

RICHARD MOSTYN

is appointed as a member of the Executive Council withresponsibility as Minister of Highways and Public Works;and Minister of the Public Service Commission.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/11 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), et à l'alinéa 2(1)b) et l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

RICHARD MOSTYN

est nommé membre du Conseil exécutif et assume lesresponsabilités suivantes : ministre de la Voirie et desTravaux publics; ministre responsable de la Commissionde la fonction publique.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

FILEDCOMMISSIONER'S ORDER 2016/12 3 December, 2016

GOVERNMENT ORGANISATION ACTYUKON ACT (CANADA)

On the advice of the Premier and pursuant to section 8 of theYukon Act (Canada), and paragraph 2(1)(b) and section 2.2of the Government Organisation Act, the Commissionerorders

JEANIE DENDYS

is appointed as a member of the Executive Council withresponsibility as Minister of Tourism and Culture;Minister responsible for the Workers' CompensationHealth and Safety Board; and Minister responsible for theWomen's Directorate.

Dated at Whitehorse, Yukon this 3 day of December, 2016.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉDÉCRET DU COMMISSAIRE 2016/12 3 décembre 2016

LOI SUR L'ORGANISATION DUGOUVERNEMENT LOI SUR LE YUKON(CANADA)

Sur l'avis du premier ministre et conformément à l'article 8de la Loi sur le Yukon (Canada), et à l'alinéa 2(1)b) et l'article2.2 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, lecommissaire ordonne :

JEANIE DENDYS

est nommée membre du Conseil exécutif et assume lesresponsabilités suivantes : ministre du Tourisme et de laCulture; ministre responsable de la Commission de lasanté et de la sécurité au travail; ministre responsable duBureau de promotion des intérêts de la femme.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 3 décembre 2016.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

21 Partie I, 15 janvier 2017

Page 23: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

PART II PARTIE IIWORKERS'

COMPENSATION HEALTHAND SAFETY BOARD

ORDER

ORDONNANCES DE LACOMMISION DE LA SANTÉ

ET DE LA SÉCURITÉ AUTRAVAIL

FILEDW.C.H.S.B.O. 2016/03 14 December, 2016

WORKERS COMPENSATION ACT

Pursuant to sections 70 and 101 of the Workers'Compensation Act, the board of directors orders

1.

The assessment classification of industries set outin the attached Schedule is established for theperiod January 1, 2017 to December 31, 2017.

2.

Workers' Compensation Health and Safety BoardOrder 2015/01 is repealed.

3.

This Order comes into force on the later of

(a) the day on which it would come into force if it were read without reference to this section; and

(b) January 1, 2017.

Dated at Whitehorse this 14 day of December, 2016.

Copies of these above mentioned materials are available for anominal fee from the Inquiry Centre, Yukon GovernmentAdministration Building, Whitehorse, Yukon. Or in writing fromQueen's Printer Subscriptions, Box 2703, Whitehorse, Yukon Y1A2C6 Canada.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉO.C.S.S.T. 2016/03 14 décembre 2016

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Conformément aux articles 70 et 101 de la Loi sur lesaccidents du travail, le conseil d'administration ordonne :

1.

L'évaluation pour les fins de la classification desindustries est établie en annexe pour la périodeallant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

2.

L'Ordonnances 2015/01 de la Commission de lasanté et de la sécurité au travail est abrogée.

3.

La présente ordonnance entre en vigueur :

a) soit à la date à laquelle elle entrerait en vigueur en l'absence du présent article;

b) soit le 1er janvier 2017, si cette date est ultérieure.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 14 décembre 2016.

Des copies des documents mentionnés ci-dessus sont disponibles,moyennant des frais symboliques, au centre de renseignements del'immeuble administratif du gouvernement du Yukon ou enécrivant au service des abonnements de l'Imprimeur de la Reine,C.P. 2703, Whitehorse, Yukon Y1A 2C6 Canada.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

Part II, January 15, 2017 22

Page 24: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

FILEDW.C.H.S.B.O. 2016/04 14 December, 2016

WORKERS COMPENSATION ACT

Pursuant to sections 69 and 101 of the Workers'Compensation Act, the board of directors orders

1.

The assessment rates per one hundred dollars ofpayroll set out in the attached Schedule areestablished for the period January 1, 2017 toDecember 31, 2017.

2.

Workers' Compensation Health and Safety BoardOrder 2015/02 is repealed.

3.

This Order comes into force on the later of

(a) the day on which it would come into force if it were read without reference to this section; and

(b) January 1, 2017.

Dated at Whitehorse this 14 day of December, 2016.

Copies of these above mentioned materials are available for anominal fee from the Inquiry Centre, Yukon GovernmentAdministration Building, Whitehorse, Yukon. Or in writing fromQueen's Printer Subscriptions, Box 2703, Whitehorse, Yukon Y1A2C6 Canada.

This notice was published in the Yukon News on December 23,2016.

DÉPOSÉO.C.S.S.T. 2016/04 14 décembre 2016

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Conformément aux articles 69 et 101 de la Loi sur lesaccidents du travail, le conseil d'administration ordonne :

1.

Sont établis les taux de cotisation, paraissant enannexe, pour chaque tranche de cent dollars de lamasse salariale, pour la période allant du 1erjanvier 2017 au 31 décembre 2017.

2.

L'Ordonnance 2015/02 de la Commission de lasanté et de la sécurité au travail est abrogée.

3.

La présente ordonnance entre en vigueur

a) soit à la date à laquelle elle entrerait en vigueur en l'absence du présent article;

b) soit le 1er janvier 2017, si cette date est ultérieure.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 14 décembre 2016.

Des copies des documents mentionnés ci-dessus sont disponibles,moyennant des frais symboliques, au centre de renseignements del'immeuble administratif du gouvernement du Yukon ou enécrivant au service des abonnements de l'Imprimeur de la Reine,C.P. 2703, Whitehorse, Yukon Y1A 2C6 Canada.

Cet avis a aussi été publié dans le Yukon News du 23 décembre2016.

23 Partie II, 15 janvier 2017

Page 25: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

January 15, 2017 24

Page 26: THE YUKON GAZETTE - Department of Highways and Public Worksgazette.gov.yk.ca/issues/2017/jan2017.pdf · 523224 Canadian Wilderness Travel Ltd. 520913 Grahams Engine & Machine Ltd

The Yukon Gazette La Gazette du Yukon

The Yukon Gazette is published on the 15th day of eachmonth. All notices intended for publication must reach theoffice of the Queen's Printer not later than 12 noon on thesecond working day of that month. The cost to the public forpublishing any notice is $20.00 plus GST, and must be paidin advance. Subscription rates are asl follows:

Annual subscription to Parts I and II,excluding index ........................................................ $65.00

Single issues, Parts I and II ........................................... $6.00

Consolidating annual indexto the 31st day of July ................................................ $12.00

(Add 5% GST to all rates)

In Part I, Corporate certificates and notices are published inthe Yukon Gazette in the language in which they are issued.

La Gazette du Yukon est publiée le 15 ème jour de chaquemois. Tous les avis destinés a être publiés doivent parvenir aubureau de l'Imprimeur de la Reine avant midi chaquedeuxième jour ouvrable du mois. Le coût de publication d'unavis est 20,000$ (TPS en sus) et doit être payé à l'avance. Lesprix pour un abonnement sont les suivants:

L'abonnement annuel aux Parties I et II,excluant l'index ........................................................ 65,00$

Un fascicule, Parties I et II ........................................... 6,00$

Index annuel compiléau 31 juillet ............................................................... 12,00$

(Veuillez ajouter 5% de TPS à tous les prix)

Les certificats et les avis concernant les sociétés diffusés dansla Partie I de la Gazette du Yukon sont publiés dans la lanbued'oigine de ces textes.

25 15 janvier 2017

ISSN 0715-2213